Home
Westovers
Gillens
News
Timelines
Videos
First Name:
Last Name:
Westover Family
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
Albums
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Share
Print
Bookmark
Note: This site uses cookies.
View policy
I understand
John Hodgson
- 1635
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
John Hodgson
[1]
d. 1 Oct 1635
Grace Ingham
b. 1606
2
Abraham Hodgeson
[1.1]
b. Abt 1621 d. 1682
Susannah Hollings
b. 3 Feb 1638 d. 1 Dec 1676
3
Susan Hodgson
[1.1.1]
b. 10 Jun 1653
William Atkinson
b. Abt 1655
4
Margaret Atkinson
[1.1.1.1]
b. 27 Mar 1682
William Harrison
c. 9 Jun 1674
5
Alice Harrison
[1.1.1.1.1]
b. 22 Aug 1726
Charles Wiseman
b. 28 Jun 1712
6
William Wiseman
[1.1.1.1.1.1]
b. 1753
Anne Gates
b. Abt 1755
7
William Gates or Wiseman
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 11 Oct 1784 d. Bef 1841
Elizabeth Adamson
b. 8 Jul 1781 d. 1856
8
Mary Ann Adamson Gates
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 5 Jul 1808 d. 22 Dec 1870
George Humble
b. 3 Nov 1804 d. 17 Jul 1869
9
George Anthony Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 22 Jan 1849 d. 10 May 1919
Olive Mehitable Cheney
b. 18 Jan 1855 d. 10 May 1938
10
Mary Ann Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 19 Jun 1870 d. 28 Sep 1930
Albert Smith, Jr
b. 11 Apr 1861 d. 29 Dec 1927
11
Mary Ann Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 12 Jul 1896 d. 14 Feb 1959
Arnold R Westover
b. 16 Mar 1895 d. 20 Jul 1971
12
Leon Arnold Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 27 Oct 1915 d. 5 Apr 1988 [
=>
]
12
Quinn Albert Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 13 Feb 1917 d. 5 Dec 1986
12
Verle George Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 27 Oct 1918 d. 19 May 1919
12
Loris Dee Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 25 Jun 1920 d. 29 Nov 2006
12
Zola Mae Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 26 Mar 1922 d. 3 May 1998
12
Artell Read Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 14 Apr 1924 d. 24 Nov 1992
12
Darrell Jay Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 23 Jan 1926 d. 20 May 2014 [
=>
]
12
Fae Yvonne Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 6 Mar 1928 d. 25 Sep 2001
12
Gordon Kent Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 25 Feb 1932 d. 30 Mar 2008
11
Olive Zenola Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 8 Aug 1892 d. 1 Sep 1948
Ray Finley Westover
b. 20 Nov 1890 d. 19 Jan 1965
12
Edna Olive Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 9 Apr 1913 d. 22 Nov 1975
12
Thelma Mary Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 29 Mar 1915 d. 8 Sep 1990
12
Reo Smith Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 11 Dec 1916 d. 30 Jan 1981
12
David Eldon Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 4 Jun 1918 d. 15 Feb 1919
12
Ruth Dawn Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 10 Aug 1920 d. 27 Aug 1982
12
Ariel Finley Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 1 Aug 1924 d. 25 Oct 1995
12
Ray Dean Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7]
b. 17 Mar 1927 d. 17 Apr 2012
12
DeVona Mae Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8]
b. 29 Apr 1932 d. 10 Oct 2002
12
Orian Keith Westover
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9]
b. 13 Apr 1934 d. 21 Mar 1968
11
Lodema Mae Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 27 May 1894 d. 4 Dec 1960
+
Elvin Daniel Thomas
b. 26 Mar 1892 d. 25 Aug 1971
11
Mark Leland Smith, Sr
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 20 Nov 1898 d. 20 Nov 1986
+
Juanna Jane Gillette
b. 12 Dec 1905 d. 25 Sep 1979
11
Talitha Cumi Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 29 May 1901 d. 31 Aug 1963
+
Alvin Jacob Teuscher
b. 21 Jan 1894 d. 6 Mar 1961
11
Caroline Elizabeth Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 27 May 1903 d. 27 May 1983
+
Le Roy Wayne Capson
b. 27 Sep 1904 d. 21 Jan 1972
11
Cecil Grant Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 10 Sep 1905 d. 14 Jan 1991
+
Ila Roberts
b. 12 Aug 1913 d. 13 Jun 1987
11
LaVada Jean Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 29 Jan 1908 d. 13 Mar 1976
+
Ralph Emanuel Nielson
b. 5 Feb 1893 d. 19 Sep 1972
11
Baby Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 7 Jun 1914 d. 7 Jun 1914
10
Olive Arletta Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 12 Feb 1872 d. 5 Jun 1931
+
John Henry Scott
b. 20 Jun 1851 d. 13 Apr 1914
+
Paul Sandoz
b. 1 Jan 1875 d. 29 May 1949
10
George Anthony Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 13 Dec 1873 d. 15 May 1874
10
Talitha Elizabeth Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 27 Mar 1875 d. 25 Apr 1942
+
John B Campbell
b. 30 Aug 1871 d. 22 Dec 1935
10
William Henry Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 28 Mar 1877 d. 27 Apr 1956
+
Agnes May Campbell
b. 6 May 1888 d. 15 Jun 1972
10
Sarah Jane Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 4 Mar 1879 d. 22 Apr 1963
+
Edwin William Butler
b. 25 Apr 1868 d. 28 Jun 1921
10
Eleanor Susanna Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 29 Jul 1882 d. 23 May 1938
+
Nathanial Campbell
b. 23 Nov 1882 d. 29 Sep 1952
10
Minnie Frances Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 22 Nov 1884 d. 30 Jul 1958
10
Eulalia Elzada Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 23 Jun 1886 d. 22 Feb 1977
+
William Ernest Westover
b. 27 Dec 1883 d. 14 Dec 1968
10
Thomas Edward Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10]
b. 15 May 1888 d. 28 Apr 1941
10
Hetty Moline Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.11]
b. 15 Sep 1891 d. 13 Jul 1927
+
Arthur Edwin Westover, Sr
b. 25 Feb 1886 d. 4 Mar 1975
10
John Scott Humble, Sr
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.12]
b. 1 Dec 1893 d. 26 Jan 1953
+
Edith Flora Kearsley
b. 12 Apr 1906 d. 19 Jun 2000
9
Frances Elizabeth Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 6 Dec 1828 d. 24 Jul 1910
+
Jacob Singleton Ferguson
b. 4 Jul 1828 d. Jan 1903
9
Elizabeth Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 10 Dec 1830 d. 10 Mar 1911
+
Jacob Singleton Ferguson
b. 4 Jul 1828 d. Jan 1903
9
Mary Ann Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1832 d. 3 Dec 1906
+
Anthony Forster Watson
b. 17 Feb 1833 d. 13 Jul 1902
9
William Thomas Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 10 Dec 1834 d. 12 Oct 1921
+
Matilda Allen
b. 19 Sep 1833 d. 6 Mar 1914
+
Marion Pfeiffer
b. 27 Nov 1843 d. 13 Oct 1919
9
Sarah Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 25 Dec 1836 d. 1895
+
Philip Jordan
b. 28 Aug 1833 d. 14 Mar 1881
9
Susannah Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 1839 d. 1840
9
Hyrum Henry Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 15 Dec 1840 d. 8 Nov 1905
+
Anne Kirstine Johansen
b. 26 Nov 1846 d. 12 Jul 1930
9
Susannah Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 1842 d. 1844
9
Jane Humble
[1.1.1.1.1.1.1.1.10]
b. 22 Jul 1845 d. 11 Jul 1921
+
Joseph Brown
b. 8 Jan 1826 d. 22 Apr 1899
8
Elizabeth Gates
[1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 18 Sep 1810 d. Apr 1893
+
Thomas Hudson
b. 1812 d. 1893
8
William Gates
[1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 22 Jun 1812 d. 1 Aug 1812
8
William Adamson Gates
[1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1814 d. 1829
8
Anthony Gates
[1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 1818
8
John Gates
[1.1.1.1.1.1.1.6]
c. 5 Nov 1820
8
Susanna Gates
[1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 1822 d. 1906
+
Joseph Dickinson
b. 1822 d. 1858
8
Jane Gates
[1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 1823 d. 5 Feb 1882
+
Richard Humble
b. 5 Jul 1818 d. 1889
8
Sarah Gates
[1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 1825 d. 1833
8
John William Gates
[1.1.1.1.1.1.1.10]
b. 1829
7
Isabella Wiseman
[1.1.1.1.1.1.2]
b. 2 Feb 1804
6
Ann Wiseman
[1.1.1.1.1.2]
b. 1748
6
Margaret Wiseman
[1.1.1.1.1.3]
b. 1749
+
Thomas Brown
b. Abt 1748 bur. 22 Feb 1824
6
Charles Wiseman
[1.1.1.1.1.4]
b. 1750
6
Alice Wiseman
[1.1.1.1.1.5]
b. 1756 d. Bef 1761
6
Jane Wiseman
[1.1.1.1.1.6]
b. 1758
6
John Wiseman
[1.1.1.1.1.7]
b. 1760
6
Alice Wiseman
[1.1.1.1.1.8]
b. 1761
6
Martin Wiseman
[1.1.1.1.1.9]
b. 1764
6
James Wiseman
[1.1.1.1.1.10]
b. 1773
6
Mary Wiseman
[1.1.1.1.1.11]
bur. 17 Aug 1758
4
John Atkinson
[1.1.1.2]
c. 19 Jul 1668
4
Henry Atkinson
[1.1.1.3]
b. 11 Feb 1669
+
Phillis Fleming
b. 10 Mar 1672
4
Elizabeth Atkinson
[1.1.1.4]
c. 1 Jan 1670 d. 11 Jan 1670
4
Elizabeth Atkinson
[1.1.1.5]
c. 23 Mar 1671
4
John Atkinson
[1.1.1.6]
c. 2 Jul 1671
4
John Atkinson
[1.1.1.7]
c. 2 Jan 1672
4
Ann Atkinson
[1.1.1.8]
c. 1 Nov 1684 bur. 14 Aug 1685
4
James Atkinson
[1.1.1.9]
3
Abraham Hodgson
[1.1.2]
c. 28 Mar 1669
+
Jane Butterworth
b. <1669>
2
John Hodgson
[1.2]
c. 18 Nov 1627
2
Susan Hodgson
[1.3]
c. chr. 21Sep1634
2
John Hodgson
[1.4]
c. chr. 01Oct1635